Date | Description |
2023-07-17 |
update robots_txt_status www.janisetaylor.com: 200 => 404 |
2021-12-10 |
update robots_txt_status www.janisetaylor.com: 404 => 200 |
2021-09-16 |
update robots_txt_status www.janisetaylor.com: 200 => 404 |
2021-09-16 |
update website_status InternalTimeout => OK |
2021-07-17 |
update website_status OK => InternalTimeout |
2021-04-19 |
delete source_ip 206.111.149.77 |
2021-04-19 |
insert source_ip 104.154.107.214 |
2021-01-30 |
insert index_pages_linkeddomain e-agents.com |
2019-06-02 |
delete address 1550 El Camino Real
Menlo Park, 94025 |
2019-06-02 |
delete email jt..@apr.com |
2019-06-02 |
delete phone 650.543.1189 |
2019-06-02 |
insert address 707 Menlo Avenue, 100
Menlo Park, CA 94025 |
2019-06-02 |
insert email jt..@parc-agency.com |
2019-06-02 |
update primary_contact 1550 El Camino Real
Menlo Park, 94025 => 707 Menlo Avenue, 100
Menlo Park, CA 94025 |
2016-10-26 |
delete index_pages_linkeddomain e-agents.com |
2016-10-26 |
delete index_pages_linkeddomain hud.gov |
2016-10-26 |
insert address 1550 El Camino Real
Menlo Park, 94025 |
2016-10-26 |
insert phone 01499609 |
2016-10-26 |
update description |
2016-09-27 |
delete address 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2016-09-27 |
insert address 2 CAROLINA LN Atherton, CA |
2016-09-27 |
update primary_contact 200 LELAND AV Menlo Park, CA => 2 CAROLINA LN Atherton, CA |
2016-08-30 |
delete address 211 PEARL LN Menlo Park, CA |
2016-08-30 |
insert address 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2016-08-30 |
update primary_contact 211 PEARL LN Menlo Park, CA => 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2016-07-27 |
delete address 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2016-07-27 |
insert address 211 PEARL LN Menlo Park, CA |
2016-07-27 |
update primary_contact 200 LELAND AV Menlo Park, CA => 211 PEARL LN Menlo Park, CA |
2016-06-28 |
delete address 470 Middlefield Road Atherton, CA |
2016-06-28 |
insert address 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2016-06-28 |
update primary_contact 470 Middlefield Road Atherton, CA => 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2016-04-23 |
delete address 2191 Gordon AVE Menlo Park, CA |
2016-04-23 |
insert address 470 Middlefield Road Atherton, CA |
2016-04-23 |
update primary_contact 2191 Gordon AVE Menlo Park, CA => 470 Middlefield Road Atherton, CA |
2016-03-22 |
insert address 2191 Gordon AVE Menlo Park, CA |
2016-03-22 |
update primary_contact null => 2191 Gordon AVE Menlo Park, CA |
2015-10-23 |
delete address 5 FOGL CT Redwood City, CA |
2015-10-23 |
update primary_contact 5 FOGL CT Redwood City, CA => null |
2015-09-25 |
delete address 351 LELAND AV Menlo Park, CA |
2015-09-25 |
insert address 5 FOGL CT Redwood City, CA |
2015-09-25 |
update primary_contact 351 LELAND AV Menlo Park, CA => 5 FOGL CT Redwood City, CA |
2015-08-28 |
insert address 351 LELAND AV Menlo Park, CA |
2015-08-28 |
update primary_contact null => 351 LELAND AV Menlo Park, CA |
2015-06-25 |
delete address 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2015-06-25 |
update primary_contact 200 LELAND AV Menlo Park, CA => null |
2015-05-18 |
delete address 770 BERKELEY AV Menlo Park, CA |
2015-05-18 |
insert address 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2015-05-18 |
update primary_contact 770 BERKELEY AV Menlo Park, CA => 200 LELAND AV Menlo Park, CA |
2015-04-19 |
delete address 1303 JOHNSON ST Menlo Park, CA |
2015-04-19 |
insert address 770 BERKELEY AV Menlo Park, CA |
2015-04-19 |
update primary_contact 1303 JOHNSON ST Menlo Park, CA => 770 BERKELEY AV Menlo Park, CA |
2015-03-22 |
insert address 1303 JOHNSON ST Menlo Park, CA |
2015-03-22 |
update primary_contact null => 1303 JOHNSON ST Menlo Park, CA |
2015-02-18 |
delete address 562 NIMITZ Avenue Redwood City, CA |
2015-02-18 |
update primary_contact 562 NIMITZ Avenue Redwood City, CA => null |
2015-01-21 |
insert address 562 NIMITZ Avenue Redwood City, CA |
2015-01-21 |
update primary_contact null => 562 NIMITZ Avenue Redwood City, CA |
2014-12-23 |
delete address 325 RAMONA Street Palo Alto, CA |
2014-12-23 |
update primary_contact 325 RAMONA Street Palo Alto, CA => null |
2014-11-23 |
delete address 562 NIMITZ Avenue Redwood City, CA |
2014-11-23 |
insert address 325 RAMONA Street Palo Alto, CA |
2014-11-23 |
update primary_contact 562 NIMITZ Avenue Redwood City, CA => 325 RAMONA Street Palo Alto, CA |
2014-10-23 |
insert address 562 NIMITZ Avenue Redwood City, CA |
2014-10-23 |
update primary_contact null => 562 NIMITZ Avenue Redwood City, CA |
2014-09-17 |
delete address 325 STANFORD AV Menlo Park, CA |
2014-09-17 |
update primary_contact 325 STANFORD AV Menlo Park, CA => null |
2014-08-12 |
insert address 325 STANFORD AV Menlo Park, CA |
2014-08-12 |
update primary_contact null => 325 STANFORD AV Menlo Park, CA |
2014-07-08 |
delete address 562 NIMITZ AV Redwood City, CA |
2014-07-08 |
update primary_contact 562 NIMITZ AV Redwood City, CA => null |
2014-05-27 |
delete address 51 INYO PL Redwood City, CA |
2014-05-27 |
insert address 562 NIMITZ AV Redwood City, CA |
2014-05-27 |
update primary_contact 51 INYO PL Redwood City, CA => 562 NIMITZ AV Redwood City, CA |
2014-04-29 |
delete address 325 STANFORD AV Menlo Park, CA |
2014-04-29 |
insert address 51 INYO PL Redwood City, CA |
2014-04-29 |
update primary_contact 325 STANFORD AV Menlo Park, CA => 51 INYO PL Redwood City, CA |
2014-03-26 |
delete address 2377 SHARON RD Menlo Park, CA |
2014-03-26 |
insert address 325 STANFORD AV Menlo Park, CA |
2014-03-26 |
update primary_contact 2377 SHARON RD Menlo Park, CA => 325 STANFORD AV Menlo Park, CA |
2014-02-05 |
insert address 2377 SHARON RD Menlo Park, CA |
2014-02-05 |
update primary_contact null => 2377 SHARON RD Menlo Park, CA |
2013-12-31 |
delete address 351 LELAND AV Menlo Park, CA |
2013-12-31 |
update primary_contact 351 LELAND AV Menlo Park, CA => null |
2013-12-03 |
insert address 351 LELAND AV Menlo Park, CA |
2013-12-03 |
update primary_contact null => 351 LELAND AV Menlo Park, CA |
2013-11-04 |
delete address 1111 MIDDLE AV Menlo Park, CA |
2013-11-04 |
update primary_contact 1111 MIDDLE AV Menlo Park, CA => null |
2013-10-07 |
delete address 562 NIMITZ AV Redwood City, CA |
2013-10-07 |
insert address 1111 MIDDLE AV Menlo Park, CA |
2013-10-07 |
update primary_contact 562 NIMITZ AV Redwood City, CA => 1111 MIDDLE AV Menlo Park, CA |
2013-08-25 |
insert about_pages_linkeddomain hud.gov |
2013-08-25 |
insert address 562 NIMITZ AV Redwood City, CA |
2013-08-25 |
insert contact_pages_linkeddomain hud.gov |
2013-08-25 |
insert index_pages_linkeddomain hud.gov |
2013-08-25 |
update primary_contact null => 562 NIMITZ AV Redwood City, CA |
2013-06-02 |
delete address 470 MIDDLEFIELD RD Atherton, CA |
2013-06-02 |
update primary_contact 470 MIDDLEFIELD RD Atherton, CA => null |
2013-04-17 |
delete address 770 BERKELEY AV Menlo Park, CA |
2013-04-17 |
insert address 470 MIDDLEFIELD RD Atherton, CA |
2013-04-17 |
update primary_contact 770 BERKELEY AV Menlo Park, CA => 470 MIDDLEFIELD RD Atherton, CA |